Trwa ładowanie...
d1y2d5l
espi
24-06-2014 18:15

AGORA - Uchwały ZWZ Agory S.A. z 24 czerwca 2014 r. (20/2014)

AGORA - Uchwały ZWZ Agory S.A. z 24 czerwca 2014 r. (20/2014)

d1y2d5l
d1y2d5l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ Agory S.A. z 24 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2014 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.931.647 ważnych głosów z 31.805.247 akcji co stanowi 62,44% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.931.647 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.931.647 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w
kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41.815.875 głosów, przeciw uchwale oddano 139.489 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 7.012.480. "Uchwała nr 3 Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad oraz inne sprawy organizacyjne. 3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013. 4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013. 5. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i
zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pani Heleny Łuczywo. 17. Zamknięcie obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.957.321 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523. "Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Panią Joannę Kosmal i Pana Jarosława Wójcika." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.402.846 ważnych głosów z 31.276.446 akcji co stanowi 61,40% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.402.846 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.402.846 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. "Uchwała nr 5 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.
1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.802.744 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 165.100. "Uchwała Nr 6 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę
48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.802.744 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 165.100. "Uchwała Nr 7 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej ,Program"). §2 1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki. 2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem. 3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 3 638 380 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału
zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały, z czego 3 271 960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela oraz 366 420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych. 4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 12 PLN (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 16 PLN (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję. 5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub dwóch) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Pierwsza oferta zostanie ogłoszona nie później niż do 29 sierpnia 2014, druga nie później niż do 30 czerwca 2015. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu. 6. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą
Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. 7. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w § 2 Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych. 8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. §3 Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu. §4 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za
przyjęciem uchwały oddano 46.749.811 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523. "Uchwała Nr 8 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. uchwala utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. 2.Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50 937 380 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.984.911 głosów, przeciw uchwale oddano 1.972.410 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523. "Uchwała Nr 9 Stosownie do
treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 1.857.129,88 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 88/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41.264.435 głosów, przeciw uchwale oddano 26.197 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 7.677.212. "Uchwała Nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 11 lutego 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 47.465.238
ważnych głosów z 30.338.838 akcji co stanowi 59,56% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 47.465.238 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.431.434 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.946.545 ważnych głosów z 31.820.145 akcji co stanowi 62,47% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.946.545 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.912.741 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Jackiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.946.545 ważnych głosów z 31.820.145 akcji co stanowi 62,47%
udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.946.545 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.912.741 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.923.393 ważnych głosów z 31.796.993 akcji co stanowi 62,42% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.923.393 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.889.589 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej,
udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.019.424 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 16 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.964.944 ważnych głosów z 31.838.544 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.964.944 ważnych głosów za
przyjęciem uchwały oddano 47.931.140 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 17 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 18 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu
Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.966.611 ważnych głosów z 31.840.211 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.966.611 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.932.807 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 19 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.
"Uchwała Nr 20 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 21 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w
kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 22 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 23 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.019.424 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 24 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.408.846 ważnych głosów z 31.282.446 akcji co stanowi 61,41% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.408.846 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.375.042 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała
Nr 25 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804. "Uchwała Nr 26 Walne Zgromadzenie postanawia dodać do par. 1 projektowanego nowego brzmienia § 18 Statutu Spółki zdanie trzecie w brzmieniu: ?Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje
czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.920.004 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.840.330. "Uchwała Nr 27 Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: (a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania
kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio (b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. (c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.728.512 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów,
wstrzymujących się głosów oddano 31.822. "Uchwała Nr 28 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały 27 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.728.512 głosów, przeciw uchwale oddano 2.228.809 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523. "Uchwała Nr 29 Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski - w miejsce Pani Heleny Łuczywo - na kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych
głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.905.195 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Resolutions adopted by Annual General Meeting of Shareholders of Agora S.A. held on June 24th, 2014 The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company") hereby announces resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders ("the General Meeting of Shareholders") convened for June 24, 2014 at 11:00 a.m. held in the Company’s registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street: "Resolution no. 1 Pursuant to the provisions of article 409 § 1 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders elected Mr. Bartosz Romanowski as the chairman of the General Meeting of Shareholders". During the voting on the resolution 48,931,647 valid votes were cast out of 31,805,247 shares, representing 62.44% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,931,647 of the valid votes 48,931,647 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. "Resolution no. 2 The General Meeting of Shareholders of Agora S.A. resolves to remove from the
agenda of the General Meeting of Shareholders announced on June 6th, 2014 points 11 and 17”. During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 41,815,875 were in favour of the resolution, 139,489 were against and 7,012,480 abstained. "Resolution no. 3 Pursuant to the provisions of § 10 point 1 of the By-laws of the general meeting of shareholders the General Meeting of Shareholders hereby approves the agenda in the following wording: 1) Opening of the General Meeting. 2) Election of the Chairman of the General Meeting, returning committee, agenda approval and other formal issues. 3) Management Board's presentation of the annual unconsolidated financial statements and the Management Board's report of the Company's activities in the fiscal year 2013, and of consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year 2013. 4)
Supervisory Board's presentation of the concise evaluation of the Company's standing in 2013. 5) Supervisory Board's presentation of the report concerning the results of evaluation of the Company's and Group's financial statements for 2013 as well as the Management Board's motion on covering loss. 6) Review and adoption of the annual unconsolidated financial statements and the Management Board's report of the Company's activities in the fiscal year 2013. 7) Review and adoption of the annual consolidated financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2013. 8) Adoption of the resolution on Company's share buyback program. 9) Adoption of the resolution on creation reserve capital for covering the cost of share buyback program. 10) Adoption of the resolution on covering the loss for the fiscal year 2013. 11) Adoption of the resolutions on approving the Management Board's performance of their duties in 2013. 12) Supervisory Board's presentation of the report on Supervisory
Board's activities in 2013, including Supervisory Board's work appraisal. 13) Adoption of the resolutions on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2013. 14) Adoption of the resolution on changing §18 item 1 of the Company's Statute. 15) Adoption of the resolution on establishing the number of Supervisory Board members. 16) Adoption of the resolution on election of the Supervisory Board's member due to the resignation of Ms. Helena Luczywo. 17) Closing of the General Meeting." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 48,957,321 were in favour of the resolution, 0 were against and 10,523 abstained. “Resolution no. 4 The Annual General Meeting hereby appoints Mrs Joanna Kosmal Mr. and Jaroslaw Wojcik to the returning committee." During the voting on the resolution 48,402,846 valid votes were cast out of 31,276,446 shares,
representing 61.40% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,402,846 of the valid votes 48,402,846 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. "Resolution no. 5 Pursuant to the provisions of article 393 point 1 and 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the non-consolidated financial statements of the Company for the fiscal year 2013 and the Management Board report on activities of the Company in the fiscal year 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 48,802,744 were in favour of the resolution, 0 were against and 165,100 abstained. "Resolution no. 6 Pursuant to the provisions of article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 55 and article 63 c item 4 of the Accounting Act, the General
Meeting of Shareholders resolves to approve the consolidated financial statements of the Agora S.A. Group for the year 2013 and the report on activities of the Agora S.A. Group in year 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 48,802,744 were in favour of the resolution, 0 were against and 165,100 abstained. "Resolution no. 7 § 1 1. The Annual General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Management Board to acquire the Company's own shares for the purpose of their redemption pursuant to art. 362 § 1 point 5 and 8 of the Commercial Companies Code subject to the conditions set forth in this resolution (hereinafter called the "Program"). §2 1. The Program comprises all the Company's shares, i.e. (i) bearer shares listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("Listed Shares") and (ii) registered shares of the Company. 2.
Acquisition of shares within the Program cannot cause the reduction of the Company's net assets below the amount of the share capital increased by the capitals that the Company cannot pay in accordance to the law or the Statutes. 3. Within the realization of the Program, the Company may acquire no more than 3 638 380 (say: three million six hundred thirty eight thousand three hundred eighty) of the shares constituting no more than 10% of the share capital of the Company as of the day of the adoption of this resolution. The total number of shares participating in the Program includes 3 271 960 (say: three million two hundred seventy one thousand nine hundred sixty) bearer shares and 366 420 (say: three hundred sixty six thousand four hundred twenty) registered shares. 4. The minimum price of a Company's share acquisition within the Program cannot be lower than PLN 12.0 (say: twelve zlotys) per one share. The maximum price of a Company's share acquisition within the Program cannot be higher than PLN 16.0 (say:
sixteen zlotys) per one share. 5. The Company's shares will be acquired by means of an offer (one or two) directed to all of the Company's shareholders. The first offer shall be announced no later than till August 29th, 2014 and the second one no later than till June 30, 2015. Pact transactions and transactions outside the regulated markets are allowed within the realization of the Program. 6. In case when the total amount of the Company's shares included in the offers of sale made by the shareholders is higher than the amount of shares that the Company plans to acquire within a given offer, the Company shall reduce the amount of shares included in the sales offers. 7. The authorization for the realization of the Program is granted for the maximum period until June 30, 2015, but no longer than up to the moment when all means meant for the realization of the Program, as set in §2 of the Resolution no. . of the Annual General Meeting of Agora S.A. dated June 24th, 2014 on creation the reserve capital to cover
the cost of Share Buyback Program, are exhausted. 8. The Management Board is entitled to take all legal and factual actions securing the execution of this resolution. §3 After the execution of the Program, the Management Board shall convene the General Meeting of Shareholders for the purpose of adoption of a resolution on redemption of shares acquired within the Program. §4 The resolution comes into force upon the day of its adoption. During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 46,749,811 were in favour of the resolution, 2,207,510 were against and 10,523 abstained. "Resolution no. 8 1. Annual General Meeting of Shareholders of Agora SA resolves to create a reserve capital to purchase own shares for the purpose of redemption. 2. Annual General Meeting of Shareholders allocates PLN 50,937,380 (say: fifty million nine hundred thirty seven thousand three
hundred eighty zlotys) from the supplementary capital for the above-mentioned reserve capital for the Share Buyback Program, and in order to finance the total value of own shares purchase. 3. The resolution shall enter into force on the date of its adoption." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 46,984,911 were in favour of the resolution, 1,972,410 were against and 10,523 abstained. "Resolution no. 9 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders resolves to cover the net loss for the fiscal year 2013 in the amount of PLN 1,857,129.88 say: (one million eight hundred fifty seven thousand one hundred twenty nine zlotys and eighty eight groszy) in total from supplementary capital." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares,
representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 41,264,435 were in favour of the resolution, 26,197 were against and 7,677,212 abstained. "Resolution no. 10 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until February 11, 2013." During the voting on the resolution 47,465,238 valid votes were cast out of 30,338,838 shares, representing 59.56% of shares in statutory capital. Out of total amount of 47,465,238 of the valid votes 46,431,434 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 11 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13
item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bak, of the performance of his duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until June 28, 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 12 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Stanisław Turnau, of the performance of his duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until June 28,
2013." During the voting on the resolution 48,946,545 valid votes were cast out of 31,820,145 shares, representing 62.47% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,946,545 of the valid votes 47,912,741 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 13 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Marek Jackiewicz, of the performance of his duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until June 28, 2013." During the voting on the resolution 48,946,545 valid votes were cast out of 31,820,145 shares, representing 62.47% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,946,545 of the valid votes 47,912,741 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no.
14 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Grzegorz Kossakowski, of the performance of his duties in 2013." During the voting on the resolution 48,923,393 valid votes were cast out of 31,796,993 shares, representing 62.42% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,923,393 of the valid votes 47,889,589 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 15 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mrs. Wanda Rapaczynski, of the performance of her duties in 2013, for
the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,053,228 valid votes were cast out of 30,926,828 shares, representing 60.72% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,053,228 of the valid votes 47,019,424 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 16 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Bartosz Hojka, of the performance of his duties in 2013, for the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,964,944 valid votes were cast out of 31,838,544 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,964,944 of the valid votes 47,931,140 were in favour of the resolution, 0 were
against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 17 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Tomasz Jagiełło, of the performance of his duties in 2013, for the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 18 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant
approval to the Management Board member, Mr. Robert Musiał, of the performance of his duties in 2013, for the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,966,611 valid votes were cast out of 31,840,211 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,966,611 of the valid votes 47,932,807 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 19 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and §13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlezak of the performance of his duties in 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and
1,033,804 abstained. "Resolution no. 20 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Marcin Hejka of the performance of his duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until June 28, 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 21 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in 2013." During the voting on the resolution
48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 22 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sławomir S. Sikora of the performance of his duties in 2013. During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 23 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of
Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Wanda Rapaczynski of the performance of her duties in 2013, for the period from January 1, 2013 until June 28, 2013." During the voting on the resolution 48,053,228 valid votes were cast out of 30,926,828 shares, representing 60.72% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,053,228 of the valid votes 47,019,424 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 24 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Helena Łuczywo of the performance of her duties in 2013, for the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,408,846 valid votes were cast out of 31,282,446 shares, representing 61.41% of shares in statutory capital. Out of total
amount of 48,408,846 of the valid votes 47,375,042 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 25 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Dariusz Formela of the performance of his duties in 2013, for the period from June 28, 2013 until December 31, 2013." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 47,934,040 were in favour of the resolution, 0 were against and 1,033,804 abstained. "Resolution no. 26 The General Meeting of Shareholders resolves to add to the draft wording § 18 point 1 of the Company’s Statute third sentence in the following wording: “ If during the term of office of the Supervisory Board a new mandate
of a Supervisory Board member is created, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with §21, second and third sentence, respectively.” During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 39,920,004 were in favour of the resolution, 2,207,510 were against and 6,840,330 abstained. "Resolution no. 27 Acting pursuant to the provisions of article 430 § 1 and § 5 of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting of Shareholders of Agora SA hereby
resolves: a) to change the Statute of the Company in the way that § 18 point 1 of the Statute reads from now on: 1. Supervisory Board consists of no less than five and no more than six members, appointed in the manner defined in § 20 and § 21, including the chairman. The number of members of the Supervisory Board is established by the General Meeting of Shareholders. If during the term of office of the Supervisory Board a new mandate of a Supervisory Board member is created, for reasons different than resignation of a Supervisory Board member, the other Supervisory Board members may appoint a new member of the Supervisory Board by means of cooption. A new member shall perform his/her functions until the General Meeting appoints a Supervisory Board member, however not longer than until the end of the common term of office of the Supervisory Board. Appointments of Supervisory Board members pursuant to this section shall comply with §21, second and third sentence, respectively. b) Supervisory Board is hereby
granted the right to determine unified text of the changed Statute. c) The Management Board of the Company is hereby obliged to notify immediately the National Court Register about the changes in the Company's Statute in order to register the changes." During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,967,844 of the valid votes 46,728,512 were in favour of the resolution, 2,207,510 were against and 31,822 abstained. "Resolution no. 28 1. Annual General Meeting of Shareholders sets the number of members of Supervisory Board for six people. 2. The resolution enters into force on the next day after the registration of resolution no. 27 of this General Meeting of Shareholders in relation to the change of § 18 point 1 of the Statute of the Company. During the voting on the resolution 48,967,844 valid votes were cast out of 31,841,444 shares, representing 62.51% of shares in statutory capital.
Out of total amount of 46,967,844 of the valid votes 46,728,512 were in favour of the resolution, 2,228,809 were against and 10,523 abstained. "Resolution no. 29 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint Mrs. Wanda Rapaczynski to the Supervisory Board of Agora S.A. - to replace Mrs. Helena Łuczywo - for the term of office which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015." During the voting on the resolution 48,053,228 valid votes were cast out of 30,926,828 shares, representing 60.72% of shares in statutory capital. Out of total amount of 48,053,228 of the valid votes 45,905,195 were in favour of the resolution, 2,137,510 were against and 10,523 abstained. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartosz Hojka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y2d5l
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1y2d5l